CALINOR. CENTRO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SL - EXTINGUIDA
Código Postal 19003
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Razón Social CALINOR. CENTRO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SL
CIF B19264779
Capital Social 233133.0 Euros
Fecha de Constitución 10/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Colegio Oficial De Aparejadores Y Arquitectos Tecn
VINCULACIONES DE CALINOR. CENTRO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALINOR. CENTRO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Arribas Villar Alberto | Secretario | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Arribas Villar Alberto | Consejero | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Colegio Oficial De Aparejadores Y Arquitectos Tecn | Socio Unico | 27/03/2009 | 20/05/2016 |
| Garcia Garcia Angel | Consejero | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Garcia Garcia Angel | Liquidador Mancomunado | 20/05/2016 | 20/05/2016 |
| Gonzalez Ruiz Manuel | Consejero | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Herranz Jarque Silvia | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Herranz Jarque Silvia | Consejero | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Leceta Fernandez Ana | Consejero | 11/07/2013 | 20/05/2016 |
| Palomeque Abad Juan | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 20/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALINOR. CENTRO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 82, S 8, H GU 7333, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 82, S 8, H GU 7333, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 82, S 8, H GU 7333, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 82, S 8, H GU 7333, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 82, S 8, H GU 7333, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 81, S 8, H GU 7333, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-19
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 81, S 8, H GU 7333, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 81, S 8, H GU 7333, I/A 3 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-19