CORPORACION QUIMICA VHEM SL - EXTINGUIDA
Código Postal 01400
Municipio Laudio/Llodio
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CORPORACION QUIMICA VHEM SL
CIF B01015221
Capital Social 1398547.86 Euros
Página Web www.nubiola.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Binder Dieter
VINCULACIONES DE CORPORACION QUIMICA VHEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION QUIMICA VHEM SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Bauer Christoph Walter | Apoderado Solidario | 21/12/2015 | 14/03/2017 |
| Binder Dieter | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 14/03/2017 |
| Binder Dieter | Presidente | 17/08/2015 | 14/03/2017 |
| Binder Dieter | Consejero | 17/08/2015 | 14/03/2017 |
| Cañizares Lopez Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2015 | 14/03/2017 |
| Castillo Arteta Angel | Consejero | 17/08/2015 | 14/03/2017 |
| Castillo Arteta Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2015 | 14/03/2017 |
| Dos Santos Patrocinio Antonio Jose | Consejero Delegado | 31/08/2015 | 14/03/2017 |
| Dos Santos Patrocinio Antonio Jose | Consejero | 31/08/2015 | 14/03/2017 |
| Frydryk Sandra Jane | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 14/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORPORACION QUIMICA VHEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 210, S 8, H VI 3152, I/A 66 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-01
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 210, S 8, H VI 3152, I/A 66 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-01
- Se modifica el artículo 7º de los estatutos sociales, en cuanto a las participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 209, S 8, H VI 3152, I/A 65 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
| Capital Anterior: | 894.362,32 | Euros |
| Aumento de capital: | 504.185,54 | Euros |
| Capital Actual: | 1.398.547,86 | Euros |
| Porcentaje: | 56,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 209, S 8, H VI 3152, I/A 65 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 209, S 8, H VI 3152, I/A 64 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 22, S 8, H VI 3152, I/A 63 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-01
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 21, S 8, H VI 3152, I/A 62 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-01
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 21, S 8, H VI 3152, I/A 61 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-01
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 21, S 8, H VI 3152, I/A 61 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-01
- Se modifican los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales referentes al capital social y a las participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 20, S 8, H VI 3152, I/A 60 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-01