EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
Municipio Langreo
Provincia Asturias
Razón Social EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
CIF B74233610
Capital Social 213006.0 Euros
Fecha de Constitución 25/04/2008
Teléfono 98 567 80 22
Página Web www.emerent.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fovini Pierre Nicola
Propietario Cgt Edilizia Spa
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/11/2025 | |
| Albasini Vincent Arthur | Consejero Delegado Solidario | 04/10/2024 | |
| Albasini Vincent Arthur | Consejero | 04/10/2024 | |
| Albasini Vincent Arthur | Consejero Delegado Mancomunado | 04/10/2024 | |
| Cgt Edilizia Spa | Socio Unico | 02/07/2024 | |
| Fernandez Pariente Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 23/10/2023 | |
| Fernandez Pariente Jose Maria | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | |
| Gonzalez Gallardo Ramon | Apoderado Mancomunado | 23/10/2023 | |
| Gonzalez Gallardo Ramon | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | |
| Martin Benitez Concepcion | Apoderado Solidario | 23/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 34 (04/11/2025)
CVE: BORME-A-2025-216-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 33 (04/11/2025)
CVE: BORME-A-2025-216-33
- CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DEL SOCIO UNICO "CGT EDILIZIA SPA" QUE PASA A DENOMINARSE "ALAYAN RENTALS SPA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 32 (26/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-101-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 31 (04/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-196-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 30 (04/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-196-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 29 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-33
- Supresión del artículo 11 bis) de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 28 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-33
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Administración y Representacion.18. Otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 28 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 38435, I/A 27 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-33
- Cambio de datos personales del Consejero, Vicepresidente del Consejo y Apoderado de la sociedad DON CLYDE DOUGLAS GRIFFIN PALMER (D.N.I. 04.737.810-V) antes DON CLYDE DOUGLAS GRIFFIN (N.I.E. Y1288165-H), por adquisición de la nacionalidad española
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4538 , F 111, S 8, H AS 38435, I/A 26 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-33