FISKARS FRANCE - EXTINGUIDA
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social FISKARS FRANCE
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 20/10/1997
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FISKARS FRANCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISKARS FRANCE
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Ana Gonzalez Orcajo | Apoderado | 21/04/2022 | 10/02/2025 |
| Carrasco Lozano Luisa | Apoderado | 21/04/2022 | 10/02/2025 |
| Cruz-villalon Garcia Diego | Apoderado | 30/11/2021 | 10/02/2025 |
| Cruz-villalon Garcia Diego | Apoderado | 21/04/2022 | 10/02/2025 |
| Cruz-villalon Garcia Diego | Apoderado | 10/02/2025 | |
| De La Cruz Fernandez Leticia | Apoderado | 30/11/2021 | 10/02/2025 |
| De La Cruz Fernandez Leticia | Apoderado | 21/04/2022 | 10/02/2025 |
| De La Cruz Fernandez Leticia | Apoderado | 10/02/2025 | |
| Denis Alexandre Jerome | Apoderado | 06/04/2023 | 10/02/2025 |
| Duhec Duhec Vanessa Andree Huguette | Apoderado | 26/07/2023 | 10/02/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FISKARS FRANCE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649580, I/A 9 (10/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-32-28
- Queda cerrada la sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649580, I/A 9 (10/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-32-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ana Gonzalez Orcajo
- Carrasco Lozano Luisa
- Cruz-villalon Garcia Diego
- Cruz-villalon Garcia Diego
- De La Cruz Fernandez Leticia
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Denis Alexandre Jerome
- Duhec Duhec Vanessa Andree Huguette
- Gallego Simon Jose Luis
- Janhunen Monika Luiza
- Kivisto Johanna Pauliina
- Marquez Gonzalez Cecilia
- Siitonen Jussi Pekka Kaarlo
- Varela Correa Laura
- Vuorinen Anna Kaisa
- Yeboue Jessica Diane Janique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649580, I/A 9 (10/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-32-28
Administrador Unico
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649580, I/A 9 (10/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 160, S 8, H M 649580, I/A 8 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 159, S 8, H M 649580, I/A 7 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 158, S 8, H M 649580, I/A 6 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 158, S 8, H M 649580, I/A 6 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 158, S 8, H M 649580, I/A 5 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 158, S 8, H M 649580, I/A 5 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28