EL MIRADOR MALL SL - EXTINGUIDA
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EL MIRADOR MALL SL
CIF B84795335
Capital Social 3052607.5 Euros
Nombres Anteriores
- GLOBAL HEIMDALL SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cortina Bv
VINCULACIONES DE EL MIRADOR MALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL MIRADOR MALL SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Cortina Bv | Socio Unico | 12/08/2013 | 20/04/2018 |
| DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
| Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
| Moya Colorado Alejandro | Administrador Unico | 18/07/2013 | 20/04/2018 |
| Newton Andrew Douglas | Apoderado | 08/10/2013 | 20/04/2018 |
| Arteaga Biforcos Alvaro | Apoderado | 08/10/2013 | |
| Bezares Del Cueto Ignacio | Apoderado | 08/10/2013 | |
| De La Vega Ortiz De La Torre Jose Maria | Apoderado | 08/10/2013 | |
| Del Riego Guzman Borja | Apoderado | 08/10/2013 | |
| Desco Menendez Carlos | Apoderado | 08/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL MIRADOR MALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 224, S 8, H M 414915, I/A 23 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 224, S 8, H M 414915, I/A 23 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 224, S 8, H M 414915, I/A 23 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 224, S 8, H M 414915, I/A 23 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 224, S 8, H M 414915, I/A 23 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 53 8& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 223, S 8, H M 414915, I/A 22 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
- CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, ACTUALMENTE "LUCHANA B.V." ANTES "CORTINA B.V."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 223, S 8, H M 414915, I/A 21 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 222, S 8, H M 414915, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Apoderado
- Arteaga Biforcos Alvaro
- Bezares Del Cueto Ignacio
- Bezares Del Cueto Ignacio
- De La Vega Ortiz De La Torre Jose Maria
- De La Vega Ortiz De La Torre Jose Maria
- Del Riego Guzman Borja
- Desco Menendez Carlos
- Diaz Almenara Sonia
- Falls Robert
- Feduchy Navarro Enrique
- Fuster Carrillo Oscar
- Gaertner Christian- Simon
- Gonzalez Espejo Garcia Alfonso
- Linares Medina Francisco Javier
- Martinez Rodriguez Mariela Rocio
- Melero Puerta Miguel Angel
- Morate Juez Javier Mariano
- Munk Alba Alfonso
- Navalon Jimenez Marcos
- Ocejo Calvo Ignacio
- Ocejo Calvo Ignacio
- Peral Guilabert Jose
- Peromingo Fresneda Miguel Angel
- Riaño Rubio Marta
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Robert Michaella
- Rodriguez Gomez Daniel
- Rodriguez Gomez Daniel
- Rodriguez Rom Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 222, S 8, H M 414915, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25104 , F 222, S 8, H M 414915, I/A 19 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28