IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL
CIF B81417057
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario LANINVER SHC SL
VINCULACIONES DE IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Barbas Fernandez Elena | Apoderado Solidario | 22/04/2016 | 30/12/2016 |
| Garcia De La Fuente Rosa Maria | Apoderado | 30/10/2012 | 30/12/2016 |
| Garcia De La Fuente Rosa Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2013 | 30/12/2016 |
| Gaude Rivelles Carlos | Apoderado | 25/06/2012 | 30/12/2016 |
| Hernandez De Aguirre Maria Begoña | Apoderado | 25/06/2012 | 30/12/2016 |
| Hernandez De Aguirre Maria Begoña | Apoderado | 30/10/2012 | 30/12/2016 |
| Holzbacher Valero Enric | Administrador Mancomunado | 14/10/2015 | 30/12/2016 |
| Holzbacher Valero Enric | Apoderado Solidario | 22/10/2015 | 30/12/2016 |
| LANINVER SHC SL | Socio Unico | 14/10/2015 | 30/12/2016 |
| Lantero Moreno Andres | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2010 | 30/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 170, S 8, H M 169992, I/A 29 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 170, S 8, H M 169992, I/A 29 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 170, S 8, H M 169992, I/A 29 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Depósito de proyecto de fusión por absorción. Sociedad absorbente: LECA PACKAGING SA. Sociedades absorbidas: TIPOGRAF SA. GRAFICAS PRINT COLOR SL. IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL. ROT CUARTA SL. LECA DIGITAL SL. IMPRIMELAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10749 , F 136, S 8, H M 169992, I/A 1M (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 170, S 8, H M 169992, I/A 28 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 170, S 8, H M 169992, I/A 27 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 169, S 8, H M 169992, I/A 26 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 168, S 8, H M 169992, I/A 25 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 168, S 8, H M 169992, I/A 25 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 168, S 8, H M 169992, I/A 25 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28