PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Massalfassar
Provincia Valencia
Razón Social PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA
CIF A46223095
Fecha de Constitución 02/09/1983
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Armengol Torrent Josep Maria
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Armengol Torrent Josep Maria | Consejero | 30/08/2013 | 23/07/2021 |
| Armengol Torrent Josep Maria | Presidente | 30/08/2013 | 23/07/2021 |
| Armengol Torrent Josep Maria | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | 23/07/2021 |
| Armengol Torrent Josep Maria | Consejero Delegado | 30/08/2013 | 23/07/2021 |
| Gil Burgos Enrique | Consejero | 30/08/2013 | 23/07/2021 |
| Pedros Riasol Josep | Consejero | 30/08/2013 | 23/07/2021 |
| PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 05/10/2011 | 23/07/2021 |
| RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 22/12/2020 | 23/07/2021 |
| Armengol Torrent Josep Maria | Consejero Delegado Solidario | 30/08/2013 | |
| Folguera Bosch Mateu | Apoderado | 27/02/2009 |
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7173, L 4476, F 138, S 8, H V 5755, I/A 75 C (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7173, L 4476, F 138, S 8, H V 5755, I/A 75 C (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7173, L 4476, F 138, S 8, H V 5755, I/A 75 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7173, L 4476, F 137, S 8, H V 5755, I/A 74 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-46
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7173, L 4476, F 136, S 8, H V 5755, I/A 73 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-46
- Sociedades absorbidas: AGROPECUARIA FRIVALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 80, S 8, H V 5755, I/A 72 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 80, S 8, H V 5755, I/A 71 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificar el Artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los Administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 79, S 8, H V 5755, I/A 70 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 79, S 8, H V 5755, I/A 69 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-46
- ARTICULO 9º.- DURACION DE CARGO.- Los miembros del consejo de administracion desempeñaran su cargo por un plazo de seis años, sin perjuicio de su reeleccion, así ocmo de la facultad de la junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitucion de los mismos de conformidad a lo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 78, S 8, H V 5755, I/A 68 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-46