RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Código Postal 46511
Municipio Benifairó de les Valls
Provincia Valencia
Razón Social RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL
CIF B97347488
Capital Social 410400.0 Euros
Fecha de Constitución 24/06/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Martinez Manzanera Diego | Administrador Mancomunado | 23/02/2017 | |
| Sanz Garcia Juan Jose | Administrador Mancomunado | 23/02/2017 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL 2004 MORAIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 6 H (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-46
- AVDA DE LES VALLS 17 1 3 - PORTA B (BENIFAIRO DE LES VALLS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 219, S 8, H V 90744, I/A 5 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-46
| Capital Anterior: | 1.423.400,00 | Euros |
| Disminución de capital | 1.013.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 410.400,00 | Euros |
| Porcentaje: | 71,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 218, S 8, H V 90744, I/A 4 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-46
- Ratificar el nombramiento realizado por el Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, en calidad de Presidente del Consejo de Administración a D. JOSE-LUIS DE LA CONCEPCION NAVARRO, como Vice-Presidente del mismo a D. JOSE-LUIS PEREZ SOLER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 218, S 8, H V 90744, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46
| Capital Anterior: | 826.400,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 597.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.423.400,00 | Euros |
| Porcentaje: | 72,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 218, S 8, H V 90744, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46
| Capital Anterior: | 1.444.400,00 | Euros |
| Disminución de capital | 618.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 826.400,00 | Euros |
| Porcentaje: | 42,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522, L 4823, F 218, S 8, H V 90744, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46