VUELTA OMEGA SL - EXTINGUIDA
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VUELTA OMEGA SL
CIF B85394310
Capital Social 680000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/03/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VUELTA OMEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VUELTA OMEGA SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|
| Aburto Uriarte Guillermo | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| Aguirregomezcorta Caubet Tatiana | Vicesecret. | 20/03/2009 | 22/12/2015 | 
| Arroyo Mira Juan Jose | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| Bros Tejedor Federico | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| Cabrera Rebato Susana | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| Castillo Navarro Reverter Paloma | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| D`hommee Caupers Pedro Jose | Presidente | 21/05/2013 | 22/12/2015 | 
| D`hommee Caupers Pedro Jose | Consejero | 22/12/2015 | |
| D'hommee Caupes Pedro-jose | Consejero | 19/05/2009 | 22/12/2015 | 
| De Castro Ribeiro Joaquin Fernando | Consejero | 09/09/2010 | 22/12/2015 | 
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VUELTA OMEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Apoderado
- Aburto Uriarte Guillermo
- Arroyo Mira Juan Jose
- Bros Tejedor Federico
- Cabrera Rebato Susana
- Castillo Navarro Reverter Paloma
- Diez Moncalvillo Angel Luis
- Dominguez Lavadores Fernando
- Durao Fernandez Alexandre Miguel
- Fernandez Pelaez Mar
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gistau Cosculluela Maria
- Gonzalez Suarez Patricica
- Izquierdo Esteban Delia
- Lobao Organista Da Sousa Mota Ana- Celeste
- Roncero Villaroya Antonio
- Sanz Jimenez Jose Florencio
- Simontalero Santurino Antonio
- Suarez Tramon Enrique Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Apoderado
- Amaro Sanchez Adolfo
- Cordero Irles Francisco
- D`hommee Caupers Pedro Jose
- De Castro Ribeiro Joaquin Fernando
- Durao Fernandes Alexandre Miguel
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Izquierdo Esteban Delia
- Martin-borregon Castañeda Jose Antonio
- Medina Barroso De Figueiredo Jose Edmundo
- Muñoz Terradez Carlos
- Sanchez Aparicio Luis
- Sanz Jimenez Jose Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 202 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 14 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
